-
PAYSAFE II LIMITED - 2 Gresham Street, 1st Floor, London, EC2V 7AD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10869730
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Gresham Street
- 1st Floor
- London
- EC2V 7AD
- England 2 Gresham Street, 1st Floor, London, EC2V 7AD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WISEMAN, Elliott Mark
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.07.2017
- Alter der Firma 2017-07-17 6 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Paysafe Group Holdings Iii Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- PI UK BIDCO LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 549300B4MPIDTD3JP548
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-29
- Letzte Einreichung: 2023-07-15
-
PAYSAFE II LIMITED Firmenbeschreibung
- PAYSAFE II LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10869730. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.07.2017 registriert. PAYSAFE II LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PI UK BIDCO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2 Gresham Street erreicht werden.
Jetzt sichern PAYSAFE II LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Paysafe Ii Limited - 2 Gresham Street, 1st Floor, London, EC2V 7AD, Grossbritannien
- 2017-07-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PAYSAFE II LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-10-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-17) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-04-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-12-21) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-12-21) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-08-10) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-06-24) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2022-06-24) - AP03
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-03) - CS01
-
resolution (2021-08-03) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-15) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-01-11) - AA
-
capital-allotment-shares (2021-09-14) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2021-09-14) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-10-06) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-11-12) - PSC05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-21) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-04-18) - AA
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2019-02-22) - CH04
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-27) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-13) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-01) - AD01
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-03-12) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-27) - AP01
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-04-12) - SH02
-
capital-allotment-shares (2018-04-12) - SH01
-
capital-redomination-of-shares (2018-02-12) - SH14
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-18) - MR01
-
resolution (2018-01-11) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-19) - TM02
-
incorporation-company (2017-07-17) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-07-25) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-31) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-07) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-13) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-13) - PSC05
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-20) - MR01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2017-11-07) - AP04
-
resolution (2017-08-01) - RESOLUTIONS