-
AWB CHARLESWORTH SOLICITORS LIMITED - 23 Otley Street, Skipton, North Yorkshire, BD23 1DY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10731478
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 23 Otley Street
- Skipton
- North Yorkshire
- BD23 1DY
- England 23 Otley Street, Skipton, North Yorkshire, BD23 1DY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DUNN, James Alexander
- GREEN, Felicity Rosemary June
- HAYES, Declan Thomas Matthew
- SHAW, Mark Robert
- TEAR, David Andrew
- VIETRI, Umberto
- BARRON, Jenny Suzanne
- COOPER, Christopher Thomas
- EAGLESFIELD, Janine Louise
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.04.2017
- Alter der Firma 2017-04-20 7 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-03
- Letzte Einreichung: 2023-04-19
-
AWB CHARLESWORTH SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- AWB CHARLESWORTH SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10731478. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.04.2017 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 9 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 23 Otley Street erreicht werden.
Jetzt sichern AWB CHARLESWORTH SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Awb Charlesworth Solicitors Limited - 23 Otley Street, Skipton, North Yorkshire, BD23 1DY, Grossbritannien
- 2017-04-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AWB CHARLESWORTH SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
resolution (2024-01-06) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2024-01-06) - SH01
keyboard_arrow_right 2023
-
resolution (2023-12-11) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2023-12-08) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2023-12-07) - SH06
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-10) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-04-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-05) - CS01
-
capital-cancellation-shares (2022-04-27) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2022-03-15) - SH03
-
resolution (2022-03-11) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2022-03-11) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2022-02-08) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2022-01-08) - SH06
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-01-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-06) - AA
-
capital-cancellation-shares (2021-10-11) - SH06
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-26) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-07-02) - TM01
-
capital-return-purchase-own-shares (2021-08-20) - SH03
-
resolution (2021-07-17) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-09) - TM01
-
capital-return-purchase-own-shares (2021-11-17) - SH03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-01) - AP01
-
capital-cancellation-shares (2021-07-16) - SH06
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-11-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-11-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-13) - AA
-
memorandum-articles (2018-10-03) - MA
-
capital-allotment-shares (2018-10-02) - SH01
-
resolution (2018-09-27) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2018-08-23) - SH01
-
resolution (2018-08-20) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
incorporation-company (2017-04-20) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-05) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-14) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-07-20) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-12) - MR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-06-14) - SH08
-
capital-allotment-shares (2017-06-02) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-08-14) - PSC08