-
VUEPAY LTD - OPUS RESTRUCTURING LLP, 1 Radian Court Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10642665
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- OPUS RESTRUCTURING LLP
- 1 Radian Court Knowlhill
- Milton Keynes
- Buckinghamshire
- MK5 8PJ OPUS RESTRUCTURING LLP, 1 Radian Court Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK5 8PJ UK
Management
- Geschäftsführung
- MCCANN, James
- PERRY, Ben
- HAATCH VENTURES DIRECTORS LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.02.2017
- Gelöscht am:
- 2023-11-03
- SIC/NACE
- 62090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr James Mccann
- Eli Nathenson
- Haatch Ventures Directors Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- LIQUID IP LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-12
- Letzte Einreichung: 2021-02-26
-
VUEPAY LTD Firmenbeschreibung
- VUEPAY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10642665. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 28.02.2017 registriert. VUEPAY LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LIQUID IP LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62090" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Opus Restructuring Llp erreicht werden.
Jetzt sichern VUEPAY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vuepay Ltd - OPUS RESTRUCTURING LLP, 1 Radian Court Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VUEPAY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-08-03) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-11-03) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-01-31) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-02-17) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-02-09) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-12-12) - AD01
-
resolution (2022-01-10) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2022-01-10) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-01-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-08) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-21) - TM01
-
capital-allotment-shares (2021-08-27) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-08-26) - PSC01
-
memorandum-articles (2021-06-22) - MA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-07-20) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2021-07-09) - SH01
-
capital-allotment-shares (2021-07-08) - SH01
-
resolution (2021-06-23) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-08-26) - PSC02
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-05) - AP01
-
capital-allotment-shares (2020-03-05) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-10) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-04-28) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-04-28) - SH02
-
capital-allotment-shares (2020-04-29) - SH01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2020-04-29) - AP02
-
resolution (2020-05-07) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-11) - PSC04
-
change-of-name-notice (2020-05-15) - CONNOT
-
resolution (2020-05-15) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-11) - AA
-
memorandum-articles (2020-05-07) - MA
-
resolution (2020-12-21) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2020-11-30) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-08) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-08) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control-without-name-date (2018-11-08) - PSC04
-
capital-allotment-shares (2018-11-08) - SH01
-
change-of-name-notice (2018-08-25) - CONNOT
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-26) - CS01
-
resolution (2018-08-25) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-17) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-03-13) - AA01
-
incorporation-company (2017-02-28) - NEWINC