-
ORCHID HOLDCO 2 LIMITED - C/O Bdo Llp 5 Temple Square, Temple Street, Liverpool, L2 5RH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10567989
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Bdo Llp 5 Temple Square
- Temple Street
- Liverpool
- L2 5RH C/O Bdo Llp 5 Temple Square, Temple Street, Liverpool, L2 5RH UK
Management
- Geschäftsführung
- FALLEN, Malcolm James
- SOMERVILLE, Martin
- STROPPA, Marcello Gabriele Arturo
- Prokuristen
- AZTEC FINANCIAL SERVICES (UK) LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.01.2017
- Alter der Firma 2017-01-17 7 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Optilan Holdco 1 Limited
- Orchid Holdco 1 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- OPTILAN HOLDCO 2 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-01-30
- Letzte Einreichung: 2023-01-16
-
ORCHID HOLDCO 2 LIMITED Firmenbeschreibung
- ORCHID HOLDCO 2 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10567989. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.01.2017 registriert. ORCHID HOLDCO 2 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen OPTILAN HOLDCO 2 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Bdo Llp 5 Temple Square erreicht werden.
Jetzt sichern ORCHID HOLDCO 2 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Orchid Holdco 2 Limited - C/O Bdo Llp 5 Temple Square, Temple Street, Liverpool, L2 5RH, Grossbritannien
- 2017-01-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ORCHID HOLDCO 2 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
resolution (2023-03-01) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-01-28) - MR04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-01-23) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2023-01-27) - CS01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-03-01) - 600
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2023-03-01) - LIQ01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-03-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-25) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-01-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-06) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2022-11-14) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2022-11-14) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-03) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
resolution (2021-03-08) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-03-04) - MA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-25) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-02-23) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-02-23) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-30) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2019-07-01) - RP04AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-22) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-03) - PSC05
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2019-05-03) - CH04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-29) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-01-30) - PSC09
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-11) - TM01
-
capital-allotment-shares (2018-08-07) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-30) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-19) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-10-08) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-15) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-20) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-08) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-02-15) - MR01
-
incorporation-company (2017-01-17) - NEWINC