-
GMT BIOGAS LIMITED - 1 The Forum, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10562584
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 The Forum
- Minerva Business Park
- Lynch Wood, Peterborough
- Cambridgeshire
- PE2 6FT
- England 1 The Forum, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6FT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GREENAWAY, Gianluca
- GREENAWAY, Philip Clive
- FENWICK, James Harding
- PASQUIER, François
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.01.2017
- Alter der Firma 2017-01-13 7 Jahre
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Philip Clive Greenaway
- Jonathon Turner
- -
- Gianluca Greenaway
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Gmt Biogas Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-10-31
- Letzte Einreichung: 2023-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-03-21
- Letzte Einreichung: 2024-03-07
-
GMT BIOGAS LIMITED Firmenbeschreibung
- GMT BIOGAS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10562584. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.01.2017 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.01.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1 The Forum erreicht werden.
Jetzt sichern GMT BIOGAS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gmt Biogas Limited - 1 The Forum, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, Grossbritannien
- 2017-01-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GMT BIOGAS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2024-03-04) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-03-04) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-03-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-03-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-03-20) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2024-03-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-10-30) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-09-04) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-09-04) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-04) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-24) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-10) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-10) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-11-10) - PSC08
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-18) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-06-06) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-19) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-19) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-02) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-02) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
incorporation-company (2017-01-13) - NEWINC
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-31) - CS01