-
LINTOTT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LIMITED - Blake House 3 Frayswater Place, Cowley, Uxbridge, Middlesex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10525620
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Blake House 3 Frayswater Place
- Cowley
- Uxbridge
- Middlesex
- UB8 2AD
- England Blake House 3 Frayswater Place, Cowley, Uxbridge, Middlesex, UB8 2AD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- OWEN, David Colin
- THUMS, Jamie
- COCKER, Neil David
- SLESSOR, Stephen James
- Prokuristen
- GALLIFORD TRY SECRETARIAT SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.12.2016
- Alter der Firma 2016-12-14 7 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Jamie Thums
- -
- -
- -
- Galliford Try (Water) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-30
- Letzte Einreichung: 2022-11-16
-
LINTOTT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LIMITED Firmenbeschreibung
- LINTOTT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10525620. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.12.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Blake House 3 Frayswater Place erreicht werden.
Jetzt sichern LINTOTT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lintott Environmental Technologies Limited - Blake House 3 Frayswater Place, Cowley, Uxbridge, Middlesex, Grossbritannien
- 2016-12-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LINTOTT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-03-22) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-09-14) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2022-01-04) - AA01
-
auditors-resignation-company (2022-01-21) - AUD
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-02-09) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-04-25) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-05-10) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-05-30) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-01-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-12-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-09) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-16) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-19) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-11-16) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-10-29) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-11-10) - AD01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2021-11-10) - AP04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-10) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-11) - AP01
-
move-registers-to-registered-office-company-with-new-address (2021-11-16) - AD04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-11-16) - PSC02
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-07) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-28) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-10-09) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-11) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-11) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-11) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-audited-abridged (2019-09-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-14) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audited-abridged (2018-09-17) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-04-11) - SH08
-
resolution (2018-04-06) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-04-11) - SH10
keyboard_arrow_right 2017
-
change-sail-address-company-with-new-address (2017-12-20) - AD02
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2017-12-20) - AD03
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-19) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2017-06-02) - SH01
-
resolution (2017-05-30) - RESOLUTIONS
-
resolution (2017-05-26) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-02-23) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-12-14) - NEWINC