-
AE TECHNOLOGY SERVICES II UK LIMITED - First Floor Office Manning House, 22 Carlisle Place, London, SW1P 1JA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10480402
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- First Floor Office Manning House
- 22 Carlisle Place
- London
- SW1P 1JA
- United Kingdom First Floor Office Manning House, 22 Carlisle Place, London, SW1P 1JA, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HARRIS, Henry Charles Robert
- HOBBY, David Philip
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.11.2016
- Alter der Firma 2016-11-15 7 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ae Corp Uk Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- LIBERTY PROPERTY CO I LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-28
- Letzte Einreichung: 2023-11-14
-
AE TECHNOLOGY SERVICES II UK LIMITED Firmenbeschreibung
- AE TECHNOLOGY SERVICES II UK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10480402. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.11.2016 registriert. AE TECHNOLOGY SERVICES II UK LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LIBERTY PROPERTY CO I LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über First Floor Office Manning House erreicht werden.
Jetzt sichern AE TECHNOLOGY SERVICES II UK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ae Technology Services Ii Uk Limited - First Floor Office Manning House, 22 Carlisle Place, London, SW1P 1JA, Grossbritannien
- 2016-11-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AE TECHNOLOGY SERVICES II UK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
legacy (2024-02-06) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2024-01-26) - AA
-
legacy (2024-01-26) - PARENT_ACC
-
legacy (2024-01-23) - GUARANTEE2
-
legacy (2024-01-13) - GUARANTEE2
-
legacy (2024-01-13) - AGREEMENT2
-
legacy (2024-01-23) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-14) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-02-04) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-01-24) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-01-19) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-11-14) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-01-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-01-10) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-08-17) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-05-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-06-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-01) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-09-07) - PSC05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-06) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2021-09-06) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-08-12) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-03-17) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-04) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-06-25) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-01) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-08) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-08) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-28) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-10) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-12-10) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-07) - AP01
-
capital-allotment-shares (2018-12-06) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-06) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-14) - CS01
-
resolution (2018-10-09) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-08) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-16) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-15) - PSC05
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-11-16) - AA01
-
incorporation-company (2016-11-15) - NEWINC