-
SELENIUM DEVELOPMENTS LIMITED - Wolffkran Limited, Grange Mill Lane, Sheffield, South Yorshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10479586
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Wolffkran Limited
- Grange Mill Lane
- Sheffield
- South Yorshire
- S9 1HW
- England Wolffkran Limited, Grange Mill Lane, Sheffield, South Yorshire, S9 1HW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COUGHTREY, Richard John
- SALT, Duncan
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.11.2016
- Alter der Firma 2016-11-15 7 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Wolffkran Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- HH CHEADLE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-28
- Letzte Einreichung: 2021-11-14
-
SELENIUM DEVELOPMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- SELENIUM DEVELOPMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10479586. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.11.2016 registriert. SELENIUM DEVELOPMENTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HH CHEADLE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Wolffkran Limited erreicht werden.
Jetzt sichern SELENIUM DEVELOPMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Selenium Developments Limited - Wolffkran Limited, Grange Mill Lane, Sheffield, South Yorshire, Grossbritannien
- 2016-11-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SELENIUM DEVELOPMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2024-01-22) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-09-30) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
resolution (2022-07-28) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2022-07-28) - LIQ01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-02-01) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-01-13) - MR04
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-07-28) - 600
keyboard_arrow_right 2021
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-12-14) - SH19
-
legacy (2021-12-14) - SH20
-
legacy (2021-12-14) - CAP-SS
-
resolution (2021-12-14) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2021-12-14) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-04) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-12-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-22) - MR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-10-26) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-10-27) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-27) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-27) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-10-27) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-20) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-11) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-10-27) - PSC07
-
memorandum-articles (2020-11-05) - MA
-
resolution (2020-11-05) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-30) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-25) - CS01
-
resolution (2019-02-08) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-25) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-08-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-04) - MR01
-
capital-allotment-shares (2019-02-15) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-02-14) - SH08
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-25) - PSC05
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-06-29) - AA
-
resolution (2018-05-24) - RESOLUTIONS
-
resolution (2018-11-28) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-21) - CS01
-
resolution (2017-06-27) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-11-22) - AA01
-
incorporation-company (2016-11-15) - NEWINC