-
DAVID BERRYMAN HOLDINGS LIMITED - 5th Floor Voyager House Chicago Avenue, Manchester Airport, Manchester, M90 3DQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10392135
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5th Floor Voyager House Chicago Avenue
- Manchester Airport
- Manchester
- M90 3DQ
- England 5th Floor Voyager House Chicago Avenue, Manchester Airport, Manchester, M90 3DQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GALLEMORE, John Andrew
- POCHIN, James Patrick
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.09.2016
- Alter der Firma 2016-09-23 7 Jahre
- SIC/NACE
- 46342
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Marianne Florence Pyrke
- The Hut.Com Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- DBH (2016) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2017-09-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-10-06
- Letzte Einreichung: 2021-09-22
-
DAVID BERRYMAN HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- DAVID BERRYMAN HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10392135. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.09.2016 registriert. DAVID BERRYMAN HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DBH (2016) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46342" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.09.2017.Die Firma kann schriftlich über 5Th Floor Voyager House Chicago Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern DAVID BERRYMAN HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: David Berryman Holdings Limited - 5th Floor Voyager House Chicago Avenue, Manchester Airport, Manchester, M90 3DQ, Grossbritannien
- 2016-09-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DAVID BERRYMAN HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-10-17) - AA
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2021-01-11) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2021-01-11) - SH08
-
resolution (2021-01-08) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-01-08) - MA
-
change-sail-address-company-with-new-address (2021-01-24) - AD02
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2021-01-25) - AD03
-
legacy (2021-10-17) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-10-17) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-23) - CS01
-
legacy (2021-10-17) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-29) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-12-09) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-09) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-11) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-12-11) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-09) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-12-11) - PSC02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-12-16) - MR04
-
capital-allotment-shares (2020-12-16) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2020-12-16) - AA01
-
resolution (2020-12-23) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-12-23) - MA
-
resolution (2020-12-24) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-01) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-30) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-09-04) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-09-04) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-22) - AA
-
resolution (2018-01-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
change-of-name-notice (2017-02-10) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2017-02-10) - CERTNM
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-19) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-19) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-25) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-11-14) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-12-04) - SH01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2016-12-01) - SH19
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-11-15) - SH08
-
legacy (2016-11-15) - SH20
-
legacy (2016-11-15) - CAP-SS
-
resolution (2016-11-15) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2016-09-23) - NEWINC
-
resolution (2016-11-11) - RESOLUTIONS