-
IMPACT SPECTRUM LTD - 1 Vicarage Lane, London, E15 4HF, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10349757
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Vicarage Lane
- London
- E15 4HF
- England 1 Vicarage Lane, London, E15 4HF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HILTON, Paul
- WELSH, Matthew
- WHITTON, Robert David
- WHITTON, Sebastian Victor
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.08.2016
- Alter der Firma 2016-08-27 7 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Hawnbrook Commercial Holdings Limited
- Impact Offices Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- TEMPLAR COMMERCIAL PROPERTY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-04
- Letzte Einreichung: 2020-10-21
-
IMPACT SPECTRUM LTD Firmenbeschreibung
- IMPACT SPECTRUM LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10349757. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.08.2016 registriert. IMPACT SPECTRUM LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TEMPLAR COMMERCIAL PROPERTY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1 Vicarage Lane erreicht werden.
Jetzt sichern IMPACT SPECTRUM LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Impact Spectrum Ltd - 1 Vicarage Lane, London, E15 4HF, England, Grossbritannien
- 2016-08-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu IMPACT SPECTRUM LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
certificate-change-of-name-company (2020-10-23) - CERTNM
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-10-21) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-22) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-10-21) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-22) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-21) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-22) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-23) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-17) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-07-31) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-07-30) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-31) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-19) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-15) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-13) - PSC04
-
capital-allotment-shares (2018-06-13) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-06-11) - SH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-24) - MR04
-
capital-allotment-shares (2018-05-23) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-23) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-02) - MR01
-
memorandum-articles (2018-02-23) - MA
-
resolution (2018-02-06) - RESOLUTIONS
-
statement-of-companys-objects (2018-02-06) - CC04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-28) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-27) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-07) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-14) - TM01
-
incorporation-company (2016-08-27) - NEWINC