-
DEERS LEAP LIMITED - C/O JAMES COWPER KRESTON, White Building 1-4 Cumberland Place, Southampton, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10267291
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O JAMES COWPER KRESTON
- White Building 1-4 Cumberland Place
- Southampton
- Hampshire
- SO15 2NP C/O JAMES COWPER KRESTON, White Building 1-4 Cumberland Place, Southampton, Hampshire, SO15 2NP UK
Management
- Geschäftsführung
- BULL, Robert
- BULL, Robert Lee Jack
- WILLIAMS, Jason Mark
- MEREDITH, Stephen Gary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.07.2016
- Alter der Firma 2016-07-07 7 Jahre
- SIC/NACE
- 55209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Raheel Khan
- -
- Dorset Caravan Park 4 Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- In Administration
- Ehemalige Namen
- BARTLEY DEVELOPMENTS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-08-31
- Letzte Einreichung: 2021-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-20
- Letzte Einreichung: 2023-07-06
-
DEERS LEAP LIMITED Firmenbeschreibung
- DEERS LEAP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10267291. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.07.2016 registriert. DEERS LEAP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BARTLEY DEVELOPMENTS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55209" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o James Cowper Kreston erreicht werden.
Jetzt sichern DEERS LEAP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Deers Leap Limited - C/O JAMES COWPER KRESTON, White Building 1-4 Cumberland Place, Southampton, Hampshire, Grossbritannien
- 2016-07-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DEERS LEAP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-in-administration-proposals (2023-10-16) - AM03
-
liquidation-in-administration-appointment-of-a-replacement-or-additional-administrator (2023-10-07) - AM11
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-08-26) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2023-08-24) - AM01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-07-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-06-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-07-12) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-06-06) - MR04
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-09-03) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-12-08) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-10) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-07-12) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-18) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-02-15) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-18) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-18) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-14) - AA01
-
resolution (2019-03-21) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2019-05-14) - MA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-18) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-08) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-09-10) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-10) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-09-13) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-08) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-08-30) - AA01
-
resolution (2019-02-06) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-20) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-20) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-13) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-09-13) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-22) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-12) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-22) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-06) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-06) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-10-20) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-18) - CS01
-
resolution (2017-03-17) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-07-07) - NEWINC