-
HFSCO LIMITED - Unit 11 Carnforth Business Park, Oakwood Way, Carnforth, LA5 9FD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10245545
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 11 Carnforth Business Park
- Oakwood Way
- Carnforth
- LA5 9FD
- United Kingdom Unit 11 Carnforth Business Park, Oakwood Way, Carnforth, LA5 9FD, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- WHILEY, George
- WHILEY, Joseph
- WHILEY, Simon
- GIBSON, Lincoln
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.06.2016
- Alter der Firma 2016-06-22 7 Jahre
- SIC/NACE
- 47530
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Simon Whiley
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- THE HARDWOOD FLOOR STORE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-09-30
- Letzte Einreichung: 2023-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-05
- Letzte Einreichung: 2023-06-21
-
HFSCO LIMITED Firmenbeschreibung
- HFSCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10245545. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.06.2016 registriert. HFSCO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen THE HARDWOOD FLOOR STORE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47530" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 11 Carnforth Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern HFSCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hfsco Limited - Unit 11 Carnforth Business Park, Oakwood Way, Carnforth, LA5 9FD, Grossbritannien
- 2016-06-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HFSCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-05-14) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-06-30) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-06-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-06-30) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2023-01-14) - SH08
-
memorandum-articles (2023-01-14) - MA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-01-06) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-01-06) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-07-20) - AA
-
resolution (2023-01-14) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-08-05) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2022-02-23) - SH08
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-25) - CH01
-
memorandum-articles (2021-02-02) - MA
-
resolution (2021-02-02) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-21) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2021-08-21) - SH08
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-08-16) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-06-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-06-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-of-name-notice (2020-08-17) - CONNOT
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-29) - TM01
-
resolution (2020-10-28) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-29) - AA
-
resolution (2020-08-17) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-16) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-10-30) - PSC09
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-29) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-11-02) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-08-06) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-16) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-08-17) - AA01
-
resolution (2018-03-27) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-07-17) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-04) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-13) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-03-27) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-06-28) - PSC08
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-06-22) - NEWINC
-
legacy (2016-09-05) - RPCH01