-
COLN SIGNATURE HOMES LIMITED - 2nd Floor 19 Apex Court Woodlands, Almondsbury Business Centre, Bristol, BS32 4JT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10208569
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor 19 Apex Court Woodlands
- Almondsbury Business Centre
- Bristol
- BS32 4JT 2nd Floor 19 Apex Court Woodlands, Almondsbury Business Centre, Bristol, BS32 4JT UK
Management
- Geschäftsführung
- BLAND, Robert Edward
- BRENNAN, Roger Anthony
- LOWE, Timothy Alun
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.06.2016
- Alter der Firma 2016-06-01 8 Jahre
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Roger Anthony Brennan
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ROWAN (295) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-03-29
- Letzte Einreichung: 2023-06-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-03-09
- Letzte Einreichung: 2024-02-23
-
COLN SIGNATURE HOMES LIMITED Firmenbeschreibung
- COLN SIGNATURE HOMES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10208569. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.06.2016 registriert. COLN SIGNATURE HOMES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ROWAN (295) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor 19 Apex Court Woodlands erreicht werden.
Jetzt sichern COLN SIGNATURE HOMES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Coln Signature Homes Limited - 2nd Floor 19 Apex Court Woodlands, Almondsbury Business Centre, Bristol, BS32 4JT, Grossbritannien
- 2016-06-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COLN SIGNATURE HOMES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-02-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2024-02-29) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-02-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-02-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-03-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-01) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-09-08) - PSC07
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-01) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-06-10) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-22) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-09-09) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-02) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-02-07) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-10-04) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-07-03) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM01
-
capital-allotment-shares (2017-09-12) - SH01
-
resolution (2017-09-07) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-21) - TM01
-
resolution (2016-06-08) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-10-29) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-10-21) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-20) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-06) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2016-09-02) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-26) - AP01
-
incorporation-company (2016-06-01) - NEWINC
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-22) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-22) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-16) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-29) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-21) - AP01
-
resolution (2016-10-28) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-22) - AP01