-
ST. ALBANS PLACE PROPCO LIMITED - 8 Sackville Street, London, W1S 3DG, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10204577
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8 Sackville Street
- London
- W1S 3DG
- England 8 Sackville Street, London, W1S 3DG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- REA, Briony Jayne
- Prokuristen
- CRESTBRIDGE UK LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.05.2016
- Alter der Firma 2016-05-27 8 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Vita Leeds 1 Devco Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- VITA LEEDS 1 LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800DY3RBZW9B2OO74
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-09
- Letzte Einreichung: 2023-05-26
-
ST. ALBANS PLACE PROPCO LIMITED Firmenbeschreibung
- ST. ALBANS PLACE PROPCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10204577. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.05.2016 registriert. ST. ALBANS PLACE PROPCO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VITA LEEDS 1 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 8 Sackville Street erreicht werden.
Jetzt sichern ST. ALBANS PLACE PROPCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: St. Albans Place Propco Limited - 8 Sackville Street, London, W1S 3DG, England, Grossbritannien
- 2016-05-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ST. ALBANS PLACE PROPCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-07-26) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-01-11) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-16) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-07-26) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-12-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-12-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-09-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-07-19) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-01-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-02-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-08) - CS01
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2021-06-08) - RP04AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-12) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-12-12) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2019-12-12) - CONNOT
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-10-04) - AA
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2019-09-24) - AP04
-
resolution (2019-09-11) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-08-28) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-29) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-06) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-06) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-08-20) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-25) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-29) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-25) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-08-25) - TM02
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-02) - MR04
-
resolution (2018-01-04) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-03) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-12-19) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-10-09) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-25) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-08) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-01-04) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-05-27) - NEWINC