-
I-MED GROUP INTERNATIONAL LIMITED - Second Floor, Poynt South, Upper Parliament Street, Nottingham, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10195860
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Second Floor
- Poynt South
- Upper Parliament Street
- Nottingham
- NG1 6LF Second Floor, Poynt South, Upper Parliament Street, Nottingham, NG1 6LF UK
Management
- Geschäftsführung
- PEPLOW, Zach
- RETTER, Simon James
- TIMPSON, Gary Edward
- Prokuristen
- RETTER, Simon James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.05.2016
- Alter der Firma 2016-05-24 8 Jahre
- SIC/NACE
- 47749
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-05-31
- Letzte Einreichung: 2018-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-06
- Letzte Einreichung: 2019-05-23
-
I-MED GROUP INTERNATIONAL LIMITED Firmenbeschreibung
- I-MED GROUP INTERNATIONAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10195860. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.05.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47749" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Second Floor erreicht werden.
Jetzt sichern I-MED GROUP INTERNATIONAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: I-Med Group International Limited - Second Floor, Poynt South, Upper Parliament Street, Nottingham, Grossbritannien
- 2016-05-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu I-MED GROUP INTERNATIONAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-02-03) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-02-04) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-07-30) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-07-10) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-07-10) - LIQ02
-
resolution (2020-07-10) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-08-16) - DISS16(SOAS)
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-08-31) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-08-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-29) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-08-29) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-08-29) - PSC08
-
gazette-notice-compulsory (2019-07-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-30) - AP01
-
capital-allotment-shares (2018-03-30) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-08) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-02-04) - SH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-08-15) - DISS40
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-30) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2018-08-14) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-05) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-05) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-12-05) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-10) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-10) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-05-10) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-05-10) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-16) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-09-19) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-09-19) - SH02
-
resolution (2017-09-15) - RESOLUTIONS
-
second-filing-capital-allotment-shares (2017-10-25) - RP04SH01
-
resolution (2017-11-01) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-11-02) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-05) - AP01
-
incorporation-company (2016-05-24) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-12) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-12) - AD01