-
TIBST LIMITED - Landmark, St Peter's Square, 1 Oxford Street, Manchester, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10174081
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Landmark
- St Peter's Square
- 1 Oxford Street
- Manchester
- M1 4PB Landmark, St Peter's Square, 1 Oxford Street, Manchester, M1 4PB UK
Management
- Geschäftsführung
- DONE, Fred
- ISMAIL, Simon Anthony
- OGDEN, Joanne Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.05.2016
- Alter der Firma 2016-05-11 8 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Fred Done
- Mr John Haynes
- Mr Naushad Islam
- Mr Simon Anthony Ismail
- -
- -
- -
- Mr Fred Done
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-20
- Letzte Einreichung: 2021-02-06
-
TIBST LIMITED Firmenbeschreibung
- TIBST LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10174081. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.05.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Landmark erreicht werden.
Jetzt sichern TIBST LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tibst Limited - Landmark, St Peter's Square, 1 Oxford Street, Manchester, Grossbritannien
- 2016-05-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TIBST LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2024-05-12) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2024-05-12) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2024-02-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-01-23) - LIQ03
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-08-22) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-09-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
resolution (2022-01-09) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-01-09) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-01-09) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2022-03-01) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-05-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-14) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-09-07) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-18) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-21) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-21) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-22) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-12-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-22) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-28) - TM01
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-06-10) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-06-14) - MR01
-
resolution (2019-06-24) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-06-25) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2019-06-26) - SH02
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-25) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-21) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-03) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-06-15) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-13) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-26) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-13) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-27) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-07) - AP01
-
incorporation-company (2016-05-11) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-11-08) - AA01