-
BERKLEY CARE (CHESHAM) LIMITED - 1st Floor, Monmouth House, Shelton Street, London, WC2H 9JN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10113365
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1st Floor, Monmouth House
- Shelton Street
- London
- WC2H 9JN
- England 1st Floor, Monmouth House, Shelton Street, London, WC2H 9JN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CAMERON, Peter Stuart
- ROBINSON, Amanda Marie
- Prokuristen
- LHJ SECRETARIES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.04.2016
- Alter der Firma 2016-04-08 8 Jahre
- SIC/NACE
- 41201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mrs Adele Dixon
- -
- -
- Ehp Bottomco Iv Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- LAWRENCE CARE (CHESHAM) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-21
- Letzte Einreichung: 2023-04-07
-
BERKLEY CARE (CHESHAM) LIMITED Firmenbeschreibung
- BERKLEY CARE (CHESHAM) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10113365. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.04.2016 registriert. BERKLEY CARE (CHESHAM) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LAWRENCE CARE (CHESHAM) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41201" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1St Floor, Monmouth House erreicht werden.
Jetzt sichern BERKLEY CARE (CHESHAM) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Berkley Care (Chesham) Limited - 1st Floor, Monmouth House, Shelton Street, London, WC2H 9JN, Grossbritannien
- 2016-04-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BERKLEY CARE (CHESHAM) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-notice-compulsory (2024-03-12) - GAZ1
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-04-22) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-04-22) - AP01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2024-04-22) - AP04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-04-19) - AD01
-
legacy (2024-04-15) - AGREEMENT2
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2024-03-20) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-04-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-04-22) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-04-22) - PSC02
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-25) - CS01
-
resolution (2023-01-24) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-10-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-10-06) - AP01
-
memorandum-articles (2023-01-24) - MA
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2022-08-11) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
resolution (2021-03-18) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-03-05) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-05) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-03-22) - MR04
-
memorandum-articles (2021-03-18) - MA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-02) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-05) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-04-19) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-05-10) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-05) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-06-22) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-05-13) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-12) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-08-14) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-16) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-07-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-09) - MR01
-
gazette-notice-compulsory (2017-06-27) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-22) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-19) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-05-11) - AA01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-06-28) - DISS40
keyboard_arrow_right 2016
-
certificate-change-of-name-company (2016-06-02) - CERTNM
-
incorporation-company (2016-04-08) - NEWINC