-
CITYSPRINT (UK) MIDCO LIMITED - C/O Interpath Ltd, 10 Fleet Place, London, EC4M 7RB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09988601
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Interpath Ltd
- 10 Fleet Place
- London
- EC4M 7RB C/O Interpath Ltd, 10 Fleet Place, London, EC4M 7RB UK
Management
- Geschäftsführung
- ASTON, Steve
- COULTON, Chris Martin
- HALFORD, Jonathan
- WEST, Gary James
- WILLIAMS, David Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.02.2016
- Gelöscht am:
- 2024-01-13
- SIC/NACE
- 64204
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Citysprint (Uk) Holdings Limited
- Citysprint (Uk) Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- FREDERICK MIDCO LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-29
- Letzte Einreichung: 2021-01-15
-
CITYSPRINT (UK) MIDCO LIMITED Firmenbeschreibung
- CITYSPRINT (UK) MIDCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09988601. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 04.02.2016 registriert. CITYSPRINT (UK) MIDCO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FREDERICK MIDCO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64204" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Interpath Ltd erreicht werden.
Jetzt sichern CITYSPRINT (UK) MIDCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Citysprint (Uk) Midco Limited - C/O Interpath Ltd, 10 Fleet Place, London, EC4M 7RB, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CITYSPRINT (UK) MIDCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2023-10-13) - LIQ13
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-05-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
resolution (2022-02-24) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-03-14) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-03-12) - 600
-
resolution (2022-03-12) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-07-04) - AD01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2022-02-24) - SH19
-
legacy (2022-02-24) - CAP-SS
-
legacy (2022-02-24) - SH20
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2022-03-12) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2021
-
legacy (2021-11-15) - AGREEMENT2
-
confirmation-statement (2021-03-31) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-03-11) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-11-15) - AA
-
legacy (2021-11-15) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-11-15) - GUARANTEE2
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2021-07-21) - RP04CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-04-22) - AA
-
legacy (2021-04-22) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-04-22) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-04-22) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-08-01) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-04) - AP01
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-08-15) - SH02
-
legacy (2020-08-19) - AGREEMENT2
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-08-16) - SH08
-
resolution (2020-08-19) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-08-19) - MA
-
legacy (2020-08-19) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-08-19) - AA
-
legacy (2020-08-19) - PARENT_ACC
-
capital-allotment-shares (2020-09-04) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-08-09) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-30) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-30) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-10-31) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-05) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-31) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-28) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-08-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-of-name-notice (2016-05-13) - CONNOT
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-08) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-24) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-23) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-20) - MR01
-
incorporation-company (2016-02-04) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-10-11) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2016-05-13) - CERTNM