-
METERS MUSIC LIMITED - The Old Maltings Hall Road, Heybridge, Maldon, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09982555
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Old Maltings Hall Road
- Heybridge
- Maldon
- Essex
- CM9 4NJ
- England The Old Maltings Hall Road, Heybridge, Maldon, Essex, CM9 4NJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GOODAY, Daniel Thomas
- GUNDERSEN, Magnus Ingolf
- RATZ, Victor Wilder
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.02.2016
- Alter der Firma 2016-02-02 8 Jahre
- SIC/NACE
- 27900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mark Alan Gooday
- Mrs Jane Elizabeth Gooday
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-17
- Letzte Einreichung: 2023-11-03
-
METERS MUSIC LIMITED Firmenbeschreibung
- METERS MUSIC LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09982555. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.02.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "27900" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Old Maltings Hall Road erreicht werden.
Jetzt sichern METERS MUSIC LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Meters Music Limited - The Old Maltings Hall Road, Heybridge, Maldon, Essex, Grossbritannien
- 2016-02-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu METERS MUSIC LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2024-01-31) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-01-31) - TM01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-05-30) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-02-13) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-02-09) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-02-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-08-11) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-08-11) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-12-13) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-09-16) - TM02
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2022-12-07) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-29) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2022-09-16) - AP03
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-12-06) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-11-06) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-15) - CS01
-
capital-allotment-shares (2020-10-08) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-09) - CS01
-
capital-allotment-shares (2020-07-09) - SH01
-
capital-allotment-shares (2020-07-07) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-17) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-28) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-11-03) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-03) - AP01
-
capital-allotment-shares (2020-11-03) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-03) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-17) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-11-03) - AP03
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-23) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-06-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-12) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-12) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-07) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-02-13) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-23) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-21) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-02-02) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2016-10-18) - SH01
-
resolution (2016-10-17) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-08-25) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-25) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-14) - CS01