-
RIGHTINDEM LIMITED - Salisbury House, 29 Finsbury Circus, London, EC2M 7AQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09943245
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Salisbury House
- 29 Finsbury Circus
- London
- EC2M 7AQ
- United Kingdom Salisbury House, 29 Finsbury Circus, London, EC2M 7AQ, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- WIRSZYCZ, Robert Michael
- SYMVAN CAPITAL LIMITED
- KAZARNOVSKY, Osher Peter
- RIGBY, Kieran Lawrence
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.01.2016
- Alter der Firma 2016-01-08 8 Jahre
- SIC/NACE
- 63120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Graham Blaney
- -
- -
- Symvan Capital Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-21
- Letzte Einreichung: 2021-01-07
-
RIGHTINDEM LIMITED Firmenbeschreibung
- RIGHTINDEM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09943245. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.01.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "63120" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Salisbury House erreicht werden.
Jetzt sichern RIGHTINDEM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rightindem Limited - Salisbury House, 29 Finsbury Circus, London, EC2M 7AQ, Grossbritannien
- 2016-01-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RIGHTINDEM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-30) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-04) - AP01
-
capital-allotment-shares (2021-01-27) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-26) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-04-25) - SH01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-21) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-01-21) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-01-21) - PSC02
-
capital-allotment-shares (2020-01-20) - SH01
-
resolution (2020-01-14) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-02) - TM01
-
capital-allotment-shares (2020-07-14) - SH01
-
capital-allotment-shares (2020-07-24) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-07) - AA
-
capital-allotment-shares (2020-10-08) - SH01
-
capital-allotment-shares (2020-12-29) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-22) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-22) - CS01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2019-04-10) - AP02
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2019-05-28) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-05-28) - SH08
-
resolution (2019-05-29) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-05-29) - SH01
-
capital-allotment-shares (2019-06-14) - SH01
-
capital-allotment-shares (2019-08-21) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-16) - TM01
-
capital-allotment-shares (2019-10-16) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-21) - AD01
-
change-corporate-director-company-with-change-date (2019-12-22) - CH02
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-19) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-12) - AD01
-
capital-allotment-shares (2018-01-19) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-01) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-19) - CS01
-
resolution (2018-01-05) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-07-09) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-01-20) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-14) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-17) - TM01
-
resolution (2017-10-27) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-13) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-12-19) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-10) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-03) - AP01
-
incorporation-company (2016-01-08) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-05-25) - AA01
-
capital-allotment-shares (2016-07-04) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2016-07-06) - AP01