-
MFF GROUP LTD - 2nd Floor Regis House, 45 King William Street, London, EC4R 9AN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09931811
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor Regis House
- 45 King William Street
- London
- EC4R 9AN
- England 2nd Floor Regis House, 45 King William Street, London, EC4R 9AN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- JONES, David
- TRIGGS, David Alfred
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.12.2015
- Alter der Firma 2015-12-30 8 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Alfred Triggs
- Mr David Jones
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-05-23
- Letzte Einreichung: 2022-05-09
-
MFF GROUP LTD Firmenbeschreibung
- MFF GROUP LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09931811. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.12.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor Regis House erreicht werden.
Jetzt sichern MFF GROUP LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mff Group Ltd - 2nd Floor Regis House, 45 King William Street, London, EC4R 9AN, Grossbritannien
- 2015-12-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MFF GROUP LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-02-28) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-06-15) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-13) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2021-05-25) - GAZ1
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-11-09) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2021-11-08) - PSC09
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-10-26) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-25) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-04-27) - CH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-12-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-18) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-01-19) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-16) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-31) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-24) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-12-04) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-21) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-22) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-26) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-09) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-02) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-07-07) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-30) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-17) - AR01
-
capital-allotment-shares (2016-05-16) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-04-04) - SH02
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-12-30) - NEWINC