-
AVENIUM ENGINEERING LTD - 3a Bowes Road Business Park, Middlesbrough, North Yorkshire, TS2 1LU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09931295
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3a Bowes Road Business Park
- Middlesbrough
- North Yorkshire
- TS2 1LU
- England 3a Bowes Road Business Park, Middlesbrough, North Yorkshire, TS2 1LU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HYNES, John Gregory
- Prokuristen
- HYNES, Kelly
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.12.2015
- Alter der Firma 2015-12-29 8 Jahre
- SIC/NACE
- 33110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr John Gregory Hynes
- -
- Mrs Rachel Styan
- Mrs Kelly Hynes
- Aviac Engineering Limited
- -
- Mrs Kelly Marie Hynes
- -
- Ivaf Holding A Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PROSAFE ENGINEERING LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-13
- Letzte Einreichung: 2021-06-29
-
AVENIUM ENGINEERING LTD Firmenbeschreibung
- AVENIUM ENGINEERING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09931295. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.12.2015 registriert. AVENIUM ENGINEERING LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PROSAFE ENGINEERING LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "33110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3A Bowes Road Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern AVENIUM ENGINEERING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Avenium Engineering Ltd - 3a Bowes Road Business Park, Middlesbrough, North Yorkshire, TS2 1LU, Grossbritannien
- 2015-12-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AVENIUM ENGINEERING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-08-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-23) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-10-08) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-11-26) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-11-25) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-19) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-03-18) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-16) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-06-10) - PSC05
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-10) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-30) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-30) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-01-31) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-14) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-27) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-03-21) - AP03
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-27) - PSC07
-
resolution (2019-03-30) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-02) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-02) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-02) - PSC05
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-06-18) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-12) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-09-19) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-01-18) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-09-12) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-06-29) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-29) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-16) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-14) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-04) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-29) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-05-18) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-06) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-06) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-20) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-20) - TM01
-
capital-allotment-shares (2016-08-01) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-12-29) - NEWINC