-
LADUMA LIMITED - C/O Lines Henry Limited 5 Tabley Court, Victoria Street, Altrincham, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09913433
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Lines Henry Limited 5 Tabley Court
- Victoria Street
- Altrincham
- Cheshire
- WA14 1EZ C/O Lines Henry Limited 5 Tabley Court, Victoria Street, Altrincham, Cheshire, WA14 1EZ UK
Management
- Geschäftsführung
- PRENDERGAST, Martin Brian
- SCHOLES, Wayne Gary James
- SUELZLE, Trevor
- ZITO, Collin, Mr.
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.12.2015
- Alter der Firma 2015-12-11 8 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Wayne Gary James Scholes
- -
- Wayne Gary James Scholes
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-01-21
- Letzte Einreichung: 2023-01-07
-
LADUMA LIMITED Firmenbeschreibung
- LADUMA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09913433. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.12.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Lines Henry Limited 5 Tabley Court erreicht werden.
Jetzt sichern LADUMA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Laduma Limited - C/O Lines Henry Limited 5 Tabley Court, Victoria Street, Altrincham, Cheshire, Grossbritannien
- 2015-12-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LADUMA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-05-07) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2024-03-26) - GAZ1
-
resolution (2024-05-07) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2024-05-07) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2024-05-07) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-05-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-19) - AA
-
resolution (2022-06-28) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-02-25) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2022-02-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-08) - CS01
-
memorandum-articles (2021-02-26) - MA
-
resolution (2021-02-26) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2021-03-02) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-18) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-10-06) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-10-06) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-12-22) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-21) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2018-12-11) - GAZ1
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-05-15) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-09) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-09) - PSC05
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-05) - PSC05
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-09) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-01-06) - SH01
-
capital-allotment-shares (2017-01-18) - SH01
-
capital-allotment-shares (2017-01-19) - SH01
-
capital-allotment-shares (2017-01-31) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-01) - AP01
-
capital-allotment-shares (2017-02-16) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-19) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-03-01) - SH01
-
capital-allotment-shares (2017-03-30) - SH01
-
capital-allotment-shares (2017-04-28) - SH01
-
capital-allotment-shares (2017-05-25) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-12-05) - AA
-
resolution (2017-02-17) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-12-07) - SH01
-
capital-allotment-shares (2016-11-03) - SH01
-
capital-allotment-shares (2016-10-12) - SH01
-
capital-allotment-shares (2016-09-08) - SH01
-
capital-allotment-shares (2016-08-17) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-29) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-24) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-12-11) - NEWINC