-
DIGITALBOX PUBLISHING LIMITED - Jubilee House, 92 Lincoln Road, Peterborough, PE1 2SN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09909897
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Jubilee House
- 92 Lincoln Road
- Peterborough
- PE1 2SN
- England Jubilee House, 92 Lincoln Road, Peterborough, PE1 2SN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CARTER, James Alexander
- DOUGLAS, James Robert
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.12.2015
- Alter der Firma 2015-12-09 8 Jahre
- SIC/NACE
- 58190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Digitalbox Publishing (Holdings) Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-22
- Letzte Einreichung: 2022-11-08
-
DIGITALBOX PUBLISHING LIMITED Firmenbeschreibung
- DIGITALBOX PUBLISHING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09909897. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.12.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58190" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Jubilee House erreicht werden.
Jetzt sichern DIGITALBOX PUBLISHING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Digitalbox Publishing Limited - Jubilee House, 92 Lincoln Road, Peterborough, PE1 2SN, Grossbritannien
- 2015-12-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DIGITALBOX PUBLISHING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-04-25) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-04-29) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-08) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-09-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-05-17) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-06-05) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-06-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-18) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-09-28) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-20) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-05-09) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-04-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-03-16) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-13) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-09) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-08-22) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-04-26) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-07) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-07) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-12-13) - AD01
-
capital-allotment-shares (2017-05-31) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-19) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-12-14) - PSC05
-
resolution (2017-07-25) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-17) - TM01
-
resolution (2017-05-25) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-06) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-01-12) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-18) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-27) - MR04
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-05-31) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-02-01) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-31) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-02-20) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-02-22) - AP03
-
legacy (2017-05-03) - RP04CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-17) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-02-16) - AP03
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-11) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-18) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-12-09) - NEWINC