-
ECOAIRBOX LIMITED - Cooper House Corbett Business Park, Stoke Prior, Bromsgrove, Worcestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09893352
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cooper House Corbett Business Park
- Stoke Prior
- Bromsgrove
- Worcestershire
- B60 4EA
- England Cooper House Corbett Business Park, Stoke Prior, Bromsgrove, Worcestershire, B60 4EA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WILLIAMS, Duncan Raymond
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.11.2015
- Alter der Firma 2015-11-30 8 Jahre
- SIC/NACE
- 28250
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Excool Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800P7H45U9QWM3L96
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-03-31
- Letzte Einreichung: 2024-03-17
-
ECOAIRBOX LIMITED Firmenbeschreibung
- ECOAIRBOX LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09893352. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.11.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "28250" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Cooper House Corbett Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern ECOAIRBOX LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ecoairbox Limited - Cooper House Corbett Business Park, Stoke Prior, Bromsgrove, Worcestershire, Grossbritannien
- 2015-11-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ECOAIRBOX LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-03-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-17) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-06-15) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-12-13) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-12-13) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-01-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-19) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-06) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-12-06) - MR04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-17) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-17) - PSC02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-17) - PSC01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control-without-name-date (2018-04-26) - PSC04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-31) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-31) - CS01
-
legacy (2018-09-26) - RP04CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-19) - CS01
-
resolution (2018-10-03) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-11-06) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-21) - PSC05
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-09-27) - SH08
keyboard_arrow_right 2017
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-28) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-22) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-27) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-11) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-31) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-10) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-27) - PSC05
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-03-09) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-09) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-03-10) - AA01
-
resolution (2016-05-31) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-06-01) - SH08
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-01) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-18) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-22) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-02) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-22) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-01) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-03-09) - TM02
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-11-30) - NEWINC