-
GLOBE MOTOR VEHICLE SPECIALISTS LIMITED - Unit 3 Devonshire Street Industrial Estate, Devonshire Street, Ardwick, Manchester, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09857762
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 3 Devonshire Street Industrial Estate
- Devonshire Street
- Ardwick
- Manchester
- M12 6AG
- England Unit 3 Devonshire Street Industrial Estate, Devonshire Street, Ardwick, Manchester, M12 6AG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CUNNINGHAM, Richard Ashton Roy
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.11.2015
- Alter der Firma 2015-11-05 8 Jahre
- SIC/NACE
- 45200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Richard Ashton Roy Cunningham
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ARAGORN HOLDINGS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-08-31
- Letzte Einreichung: 2019-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-18
- Letzte Einreichung: 2020-11-04
-
GLOBE MOTOR VEHICLE SPECIALISTS LIMITED Firmenbeschreibung
- GLOBE MOTOR VEHICLE SPECIALISTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09857762. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.11.2015 registriert. GLOBE MOTOR VEHICLE SPECIALISTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ARAGORN HOLDINGS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45200" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 3 Devonshire Street Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern GLOBE MOTOR VEHICLE SPECIALISTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Globe Motor Vehicle Specialists Limited - Unit 3 Devonshire Street Industrial Estate, Devonshire Street, Ardwick, Manchester, Grossbritannien
- 2015-11-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GLOBE MOTOR VEHICLE SPECIALISTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-11-06) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2021-11-02) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-11) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-14) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-08-31) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-08-29) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2019-06-04) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-02-05) - DISS40
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-04) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-16) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-12-07) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2018-10-30) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-16) - AP01
-
notice-of-removal-of-a-director (2018-03-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-07) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-01) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-15) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-23) - CS01
-
capital-allotment-shares (2016-11-23) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-23) - AP01
-
resolution (2016-07-07) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-11-05) - NEWINC