-
AZETS (GLOUCESTER) LIMITED - 2nd Floor Regis House, 45 King William Street, London, EC4R 9AN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09837262
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor Regis House
- 45 King William Street
- London
- EC4R 9AN
- England 2nd Floor Regis House, 45 King William Street, London, EC4R 9AN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- NORRIS, Adrian Mark
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.10.2015
- Gelöscht am:
- 2023-04-04
- SIC/NACE
- 69201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Baldwins Holdings Ltd
- Azets Holdings Ltd
- Azets Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- BALDWINS (GLOUCESTER) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2021-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-04
- Letzte Einreichung: 2021-10-21
-
AZETS (GLOUCESTER) LIMITED Firmenbeschreibung
- AZETS (GLOUCESTER) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09837262. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 22.10.2015 registriert. AZETS (GLOUCESTER) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BALDWINS (GLOUCESTER) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69201" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor Regis House erreicht werden.
Jetzt sichern AZETS (GLOUCESTER) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Azets (Gloucester) Limited - 2nd Floor Regis House, 45 King William Street, London, EC4R 9AN, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AZETS (GLOUCESTER) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2023-02-14) - SOAS(A)
-
gazette-dissolved-voluntary (2023-04-04) - GAZ2(A)
-
gazette-notice-voluntary (2023-01-17) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-01-06) - DS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
legacy (2022-12-20) - SH20
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-28) - AA
-
legacy (2022-12-20) - CAP-SS
-
resolution (2022-12-20) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-21) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-10-02) - AD01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2022-12-20) - SH19
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-28) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-05-06) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-06-28) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-09-08) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-06-25) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-10-21) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-21) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-06-19) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-12-17) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-13) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-28) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-09-24) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-03-27) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-12) - TM01
-
auditors-resignation-company (2018-01-25) - AUD
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-04-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-30) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-09) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-30) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-06) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-04-21) - MR04
-
resolution (2016-04-25) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2016-04-25) - MA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-09-21) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-10-22) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-10) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-12-03) - SH01
-
resolution (2015-12-03) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-03) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-26) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-20) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-12-15) - AP03
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-12-03) - SH08