-
CENT INVESTMENTS LIMITED - Bank House, 81 St Judes Road, Englefield Green, TW20 0DF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09832358
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bank House
- 81 St Judes Road
- Englefield Green
- TW20 0DF
- United Kingdom Bank House, 81 St Judes Road, Englefield Green, TW20 0DF, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIS, Liesl
- SILVESTER, Dominic Francis Michael
- SILVESTER, Julie Patricia
- Prokuristen
- EXCEED COSEC SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.10.2015
- Alter der Firma 2015-10-20 8 Jahre
- SIC/NACE
- 64304
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Dominic Francis Michael Silvester
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 2138003ZV2JN5TCC1B15
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-08-11
- Letzte Einreichung: 2021-07-28
-
CENT INVESTMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- CENT INVESTMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09832358. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.10.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64304" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Bank House erreicht werden.
Jetzt sichern CENT INVESTMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cent Investments Limited - Bank House, 81 St Judes Road, Englefield Green, TW20 0DF, Grossbritannien
- 2015-10-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CENT INVESTMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-06-05) - LIQ03
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-03-03) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-04-23) - MR04
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2022-04-09) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-04-09) - 600
-
resolution (2022-04-09) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-03-15) - MR04
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-15) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-09-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-20) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-07-28) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-28) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-07-23) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-23) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-15) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-07-15) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-04-26) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-03-31) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-31) - CH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-07-28) - PSC07
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-07) - AAMD
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-01) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-08-25) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-02-27) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-23) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-09-12) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-11-11) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-10-18) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-31) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-22) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-05-08) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-16) - MR01
-
capital-allotment-shares (2017-04-07) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-29) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-03) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2015-10-21) - AP04
-
incorporation-company (2015-10-20) - NEWINC