-
IRRESISTIBLE GROUP LIMITED - 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London, N21 3NA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09830994
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Kings Avenue
- Winchmore Hill
- London
- N21 3NA
- England 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London, N21 3NA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DUNLOP, Daniel John
- DUNLOP, Gail Deborah
- Prokuristen
- PATTINSON, Leonard James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.10.2015
- Alter der Firma 2015-10-19 8 Jahre
- SIC/NACE
- 74100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Jon Wylson
- Mrs Gail Deborah Dunlop
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-01
- Letzte Einreichung: 2023-10-18
-
IRRESISTIBLE GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- IRRESISTIBLE GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09830994. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.10.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1 Kings Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern IRRESISTIBLE GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Irresistible Group Limited - 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London, N21 3NA, Grossbritannien
- 2015-10-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu IRRESISTIBLE GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-11-20) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2023-09-30) - AA01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-01-28) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-27) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2023-01-17) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-01) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-10-12) - PSC04
-
capital-return-purchase-own-shares (2022-01-25) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2022-01-24) - SH06
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2022-01-21) - RP04CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-19) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-01-20) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2022-01-11) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-01-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-06) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
memorandum-articles (2020-06-09) - MA
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-06-09) - SH08
-
resolution (2020-06-09) - RESOLUTIONS
-
resolution (2020-07-10) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2020-06-09) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-29) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-12-06) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-26) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-26) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-07-30) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-30) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-07-31) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-05) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-26) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-26) - AP01
-
incorporation-company (2015-10-19) - NEWINC