-
PRFI LIMITED - Oval Park Hatfield Road, Langford, Maldon, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09826758
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Oval Park Hatfield Road
- Langford
- Maldon
- Essex
- CM9 6WG
- England Oval Park Hatfield Road, Langford, Maldon, Essex, CM9 6WG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DEVLIN, Liam Michael
- CLARK, Nigel Graham
- GURRY, Christopher Arthur
- MCCABE, Mark John
- Prokuristen
- JONES, Michelle
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.10.2015
- Alter der Firma 2015-10-15 8 Jahre
- SIC/NACE
- 71122
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Timothy Jackson
- -
- Cml Microsystems Plc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PLEXTEK RFI LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-02-28
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-11-25
- Letzte Einreichung: 2019-10-14
-
PRFI LIMITED Firmenbeschreibung
- PRFI LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09826758. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.10.2015 registriert. PRFI LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PLEXTEK RFI LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71122" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Oval Park Hatfield Road erreicht werden.
Jetzt sichern PRFI LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Prfi Limited - Oval Park Hatfield Road, Langford, Maldon, Essex, Grossbritannien
- 2015-10-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PRFI LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
capital-allotment-shares (2020-04-23) - SH01
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-01-29) - SH03
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2020-01-28) - SH10
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-05) - AA
-
resolution (2020-01-29) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-03-19) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-17) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-03-03) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-03) - TM01
-
capital-cancellation-shares (2020-01-29) - SH06
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-03) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-03) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-03-03) - AP03
-
resolution (2020-07-03) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-03) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-03) - PSC02
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-07) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-08-08) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-08-08) - AP03
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-08-22) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-08-22) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-10-31) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-16) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-09-27) - MR04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-06-14) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-06-14) - AP03
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-17) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-22) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-06-14) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-06) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-10-15) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-19) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-10-19) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-19) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-10-19) - TM02
-
resolution (2015-12-09) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-12-09) - SH02
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-12-09) - SH08
-
resolution (2015-12-31) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-12-31) - SH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-10-19) - AP03