-
FMP HR AND PAYROLL SOFTWARE LIMITED - 4th Floor, Heathrow Approach, 470 London Road, Slough, SL3 8QY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09811970
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th Floor, Heathrow Approach
- 470 London Road
- Slough
- SL3 8QY
- England 4th Floor, Heathrow Approach, 470 London Road, Slough, SL3 8QY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COX, Michael David
- DADY, Kevin Peter
- LOCKIE, David James
- MORTIMER-ZHIKA, Elona
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.10.2015
- Alter der Firma 2015-10-06 8 Jahre
- SIC/NACE
- 69202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Fmp Global Bidco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- BOND HR AND PAYROLL SOFTWARE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-01-31
- Letzte Einreichung: 2022-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-10
- Letzte Einreichung: 2023-05-27
-
FMP HR AND PAYROLL SOFTWARE LIMITED Firmenbeschreibung
- FMP HR AND PAYROLL SOFTWARE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09811970. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.10.2015 registriert. FMP HR AND PAYROLL SOFTWARE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BOND HR AND PAYROLL SOFTWARE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69202" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4Th Floor, Heathrow Approach erreicht werden.
Jetzt sichern FMP HR AND PAYROLL SOFTWARE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fmp Hr And Payroll Software Limited - 4th Floor, Heathrow Approach, 470 London Road, Slough, SL3 8QY, Grossbritannien
- 2015-10-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FMP HR AND PAYROLL SOFTWARE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
legacy (2024-01-20) - PARENT_ACC
-
legacy (2024-01-18) - AGREEMENT2
-
legacy (2024-01-18) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-01-05) - AA
-
legacy (2023-01-05) - PARENT_ACC
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
legacy (2022-10-12) - GUARANTEE2
-
legacy (2022-10-12) - AGREEMENT2
-
legacy (2022-09-06) - AGREEMENT2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-09) - CS01
-
legacy (2022-02-02) - PARENT_ACC
-
legacy (2022-02-02) - GUARANTEE2
-
legacy (2022-02-02) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2022-01-27) - AA
-
legacy (2022-01-08) - PARENT_ACC
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-02-19) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-01) - CH01
-
legacy (2021-11-01) - AGREEMENT2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-09) - CS01
-
legacy (2021-11-01) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-08) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-24) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-12-11) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-23) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-11) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-11) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-24) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-24) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-07-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-07-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-22) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-11) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-06) - MR01
-
change-of-name-notice (2016-01-22) - CONNOT
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-13) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2016-01-22) - CERTNM
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-08-23) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-01) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-09-01) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-01) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-02) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-17) - CS01
-
resolution (2016-10-25) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-10-06) - NEWINC