-
MINTINI BABY LIMITED - Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09795147
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Greg's Building
- 1 Booth Street
- Manchester
- M2 4DU Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU UK
Management
- Geschäftsführung
- BLOOM, Vincent
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.09.2015
- Alter der Firma 2015-09-25 8 Jahre
- SIC/NACE
- 46420
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Harcastle Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-11-07
- Letzte Einreichung: 2019-09-26
-
MINTINI BABY LIMITED Firmenbeschreibung
- MINTINI BABY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09795147. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.09.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46420" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Greg's Building erreicht werden.
Jetzt sichern MINTINI BABY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mintini Baby Limited - Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
- 2015-09-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MINTINI BABY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-08-05) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-07-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-07-28) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-disclaimer-notice (2020-08-14) - NDISC
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-12) - MR04
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-05-30) - 600
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-30) - TM01
-
resolution (2020-05-30) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-05-18) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-05-30) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-15) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-30) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-12-11) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-19) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-26) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-26) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-20) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-14) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-03-15) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-10) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-26) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-25) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-09-25) - NEWINC