-
NJF PROPCO LIMITED - 2nd Floor 27 Albemarle Street, London, W1S 4HZ, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09705116
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor 27 Albemarle Street
- London
- W1S 4HZ
- England 2nd Floor 27 Albemarle Street, London, W1S 4HZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FARRELL, Matthew Martin
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.07.2015
- Alter der Firma 2015-07-27 8 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Njf Property Holdco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-27
- Letzte Einreichung: 2021-06-13
-
NJF PROPCO LIMITED Firmenbeschreibung
- NJF PROPCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09705116. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.07.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor 27 Albemarle Street erreicht werden.
Jetzt sichern NJF PROPCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Njf Propco Limited - 2nd Floor 27 Albemarle Street, London, W1S 4HZ, England, Grossbritannien
- 2015-07-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NJF PROPCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-17) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-17) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-02-14) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-18) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-06) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-06) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-07) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-08-30) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-03-07) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-07) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-27) - CS01
-
resolution (2018-09-10) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-08-28) - MR04
-
resolution (2018-09-20) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2018-09-20) - MA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-17) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-07) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-10-12) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-18) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-05) - MR01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2016-04-27) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-04-28) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-28) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-11-01) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-28) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-28) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-17) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-15) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-15) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2016-08-16) - CH04
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-08-28) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-08-27) - AA01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-07-27) - AA01
-
incorporation-company (2015-07-27) - NEWINC