-
VILLAGE VET HOLDING LIMITED - Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09691740
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Friars Gate
- 1011 Stratford Road
- Shirley
- West Midlands
- B90 4BN
- United Kingdom Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, West Midlands, B90 4BN, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- REIDY, Ray Andrew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.07.2015
- Alter der Firma 2015-07-17 8 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Village Vet Newco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-30
- Letzte Einreichung: 2020-07-16
-
VILLAGE VET HOLDING LIMITED Firmenbeschreibung
- VILLAGE VET HOLDING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09691740. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.07.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Friars Gate erreicht werden.
Jetzt sichern VILLAGE VET HOLDING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Village Vet Holding Limited - Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, West Midlands, Grossbritannien
- 2015-07-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VILLAGE VET HOLDING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2021-02-09) - LIQ01
-
resolution (2021-02-09) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-02-09) - 600
-
change-to-a-person-with-significant-control-without-name-date (2021-10-14) - PSC04
-
legacy (2021-01-11) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control-without-name-date (2020-02-12) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-20) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-27) - PSC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-04) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-07) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-29) - CH01
-
change-sail-address-company-with-new-address (2019-01-30) - AD02
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2019-02-01) - AD03
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-03-06) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-10) - TM01
-
resolution (2019-12-13) - RESOLUTIONS
-
legacy (2019-12-13) - CAP-SS
-
legacy (2019-12-13) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-12-13) - SH19
-
capital-allotment-shares (2019-12-18) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-23) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-07-16) - PSC05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-15) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-06-23) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-08-06) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-12-12) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-05) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-04-20) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-12) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-13) - TM01
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-06-23) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2017-06-23) - SH10
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-05) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-07-05) - PSC05
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-07-27) - PSC05
-
resolution (2017-06-20) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-06) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-07-26) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-22) - AP01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-04-22) - SH02
-
capital-allotment-shares (2016-04-22) - SH01
-
resolution (2016-04-22) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-07-17) - NEWINC