-
D.B. SYSTEMS HOLDINGS LIMITED - Spectrum 800 Ashchurch Business Park, Alexandra Way, Tewkesbury, Gloucestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09648624
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Spectrum 800 Ashchurch Business Park
- Alexandra Way
- Tewkesbury
- Gloucestershire
- GL20 8TD Spectrum 800 Ashchurch Business Park, Alexandra Way, Tewkesbury, Gloucestershire, GL20 8TD UK
Management
- Geschäftsführung
- BULLEY, David Charles
- BURGESS, Anthony John
- MACLEAY, James Alister
- REECE, Alastair
- WAKEFIELD, James Christopher
- BARNETT, James Ellis Lever
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.06.2015
- Alter der Firma 2015-06-19 8 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CROSERVICE CO 5 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-03
- Letzte Einreichung: 2021-06-19
-
D.B. SYSTEMS HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- D.B. SYSTEMS HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09648624. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.06.2015 registriert. D.B. SYSTEMS HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CROSERVICE CO 5 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Spectrum 800 Ashchurch Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern D.B. SYSTEMS HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: D.b. Systems Holdings Limited - Spectrum 800 Ashchurch Business Park, Alexandra Way, Tewkesbury, Gloucestershire, Grossbritannien
- 2015-06-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu D.B. SYSTEMS HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-04-01) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-26) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-26) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-11-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-01-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-16) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-02) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-02-06) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-12) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-10-18) - SH08
-
resolution (2018-10-18) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-03) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-10) - PSC08
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-06) - TM01
-
capital-cancellation-shares (2017-06-12) - SH06
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-11-23) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-06-29) - SH03
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-11-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-23) - MR01
-
incorporation-company (2015-06-19) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2015-12-04) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-04) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-12-04) - AA01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-12-04) - SH08
-
resolution (2015-12-04) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-04) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2015-12-03) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2015-12-03) - CONNOT
-
capital-allotment-shares (2015-12-03) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-16) - MR01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-12-04) - SH02