-
LOW BURNTOFT SOLAR LIMITED - 15 Diddenham Court Lambwood Hill, Grazeley, Reading, RG7 1JQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09646505
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 15 Diddenham Court Lambwood Hill
- Grazeley
- Reading
- RG7 1JQ
- England 15 Diddenham Court Lambwood Hill, Grazeley, Reading, RG7 1JQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HILDYARD, Nigel David
- SKINNER, Julian Norman Thomas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.06.2015
- Alter der Firma 2015-06-18 8 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Daedalus Acquisitions Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-25
- Letzte Einreichung: 2020-06-11
-
LOW BURNTOFT SOLAR LIMITED Firmenbeschreibung
- LOW BURNTOFT SOLAR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09646505. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.06.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 15 Diddenham Court Lambwood Hill erreicht werden.
Jetzt sichern LOW BURNTOFT SOLAR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Low Burntoft Solar Limited - 15 Diddenham Court Lambwood Hill, Grazeley, Reading, RG7 1JQ, Grossbritannien
- 2015-06-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LOW BURNTOFT SOLAR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-01-06) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-15) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-30) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-03) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-04) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-16) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-30) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-19) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-13) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-29) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-14) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-17) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-05) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-08) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-12) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-12) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-07-14) - AA01
-
resolution (2016-07-19) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-06-18) - NEWINC