-
BLUESYS IT SERVICES LTD - Unit H1, Risby Business Park Newmarket Road, Risby, Bury St Edmunds, Suffolk, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09634356
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit H1, Risby Business Park Newmarket Road
- Risby
- Bury St Edmunds
- Suffolk
- IP28 6RD
- United Kingdom Unit H1, Risby Business Park Newmarket Road, Risby, Bury St Edmunds, Suffolk, IP28 6RD, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- GAY, Simon John
- WITHERS, Iain Mark
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.06.2015
- Alter der Firma 2015-06-11 9 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Bluesys Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- SICON NETWORK SERVICES LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-25
- Letzte Einreichung: 2023-06-11
-
BLUESYS IT SERVICES LTD Firmenbeschreibung
- BLUESYS IT SERVICES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09634356. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.06.2015 registriert. BLUESYS IT SERVICES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SICON NETWORK SERVICES LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit H1, Risby Business Park Newmarket Road erreicht werden.
Jetzt sichern BLUESYS IT SERVICES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bluesys It Services Ltd - Unit H1, Risby Business Park Newmarket Road, Risby, Bury St Edmunds, Suffolk, Grossbritannien
- 2015-06-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLUESYS IT SERVICES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-06-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-19) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-30) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-07-30) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-06-16) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-04-06) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-15) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-12-17) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-11-06) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-28) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-07-09) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-14) - CS01
-
resolution (2018-01-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-29) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-29) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-21) - MR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-09-28) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-06-11) - NEWINC