-
KOBOX LIMITED - Unit 4 122a Gloucester Avenue, London, NW1 8HX, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09623350
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 4 122a Gloucester Avenue
- London
- NW1 8HX
- United Kingdom Unit 4 122a Gloucester Avenue, London, NW1 8HX, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ALOM, Mohammed Tuhel
- COTTAM, Jonathan Daniel Nicholas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.06.2015
- Alter der Firma 2015-06-04 8 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- United Fitness Brands Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- KOBOX LONDON LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-05
- Letzte Einreichung: 2023-04-21
-
KOBOX LIMITED Firmenbeschreibung
- KOBOX LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09623350. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.06.2015 registriert. KOBOX LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen KOBOX LONDON LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 4 122A Gloucester Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern KOBOX LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kobox Limited - Unit 4 122a Gloucester Avenue, London, NW1 8HX, United Kingdom, Grossbritannien
- 2015-06-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KOBOX LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-22) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-01-25) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-01-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-03-31) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-05-05) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-05-05) - PSC05
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-04-06) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2022-04-06) - PSC09
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-01-25) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-09-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-15) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-09-07) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-09-15) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-16) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-09-17) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-09-20) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-17) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-07-29) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-09-24) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-24) - PSC07
-
resolution (2018-10-01) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-24) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-01) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-10-19) - PSC08
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-24) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-23) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-06-20) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-27) - TM01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-28) - PSC09
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-26) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-08) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-02-15) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-02-21) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-10) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-09) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2016-02-27) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-11) - MR01
-
change-of-name-notice (2016-02-27) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-04) - CH01
-
incorporation-company (2015-06-04) - NEWINC