-
4FRONT HEALTHCARE LIMITED - C/O Dow Scofield Watts Business Recovery Llp, 7400 Daresbury Park, Daresbury, Warrington, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09618700
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Dow Scofield Watts Business Recovery Llp
- 7400 Daresbury Park
- Daresbury
- Warrington
- WA4 4BS C/O Dow Scofield Watts Business Recovery Llp, 7400 Daresbury Park, Daresbury, Warrington, WA4 4BS UK
Management
- Geschäftsführung
- MUNRO, Ian James
- SEED CAP HOLDINGS LIMITED
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.06.2015
- Gelöscht am:
- 2021-08-14
- SIC/NACE
- 78200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Seed Cap Holdings Limited
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-12-11
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-04-14
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
-
4FRONT HEALTHCARE LIMITED Firmenbeschreibung
- 4FRONT HEALTHCARE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09618700. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 02.06.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Dow Scofield Watts Business Recovery Llp erreicht werden.
Jetzt sichern 4FRONT HEALTHCARE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 4Front Healthcare Limited - C/O Dow Scofield Watts Business Recovery Llp, 7400 Daresbury Park, Daresbury, Warrington, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 4FRONT HEALTHCARE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-08-14) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-05-14) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-05-13) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-03-25) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-03-25) - LIQ02
-
resolution (2019-03-25) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-09-11) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-03) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-10-18) - MR04
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2018-10-22) - AP02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-22) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-24) - MR01
-
memorandum-articles (2018-08-28) - MA
-
resolution (2018-10-24) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-10) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-10) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-22) - TM01
-
resolution (2018-08-28) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-05-22) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-03) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-13) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-09) - MR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-06-09) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-16) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-06-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-17) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-11) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-02) - PSC05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-08-25) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-23) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-06-02) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-08-25) - AA01