-
VINE HOTELS LIMITED - C/O Director Of Finance Kenwood Hall Hotel, Kenwood Road, Sheffield, S7 1NQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09606831
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Director Of Finance Kenwood Hall Hotel
- Kenwood Road
- Sheffield
- S7 1NQ
- United Kingdom C/O Director Of Finance Kenwood Hall Hotel, Kenwood Road, Sheffield, S7 1NQ, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BURGIN, Neil
- DAVIES, Garin James
- DYKE, Gregory
- HOWES, Susan
- Prokuristen
- BURGIN, Neil
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.05.2015
- Alter der Firma 2015-05-26 9 Jahre
- SIC/NACE
- 55100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Susan Howes
- -
- Mrs Susan Howes
- Mr Gregory Dyke
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-03-24
- Letzte Einreichung: 2022-03-10
-
VINE HOTELS LIMITED Firmenbeschreibung
- VINE HOTELS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09606831. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.05.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Director Of Finance Kenwood Hall Hotel erreicht werden.
Jetzt sichern VINE HOTELS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vine Hotels Limited - C/O Director Of Finance Kenwood Hall Hotel, Kenwood Road, Sheffield, S7 1NQ, Grossbritannien
- 2015-05-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VINE HOTELS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-12-23) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-03-03) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-10) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-03-10) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-04-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-06-01) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-01) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-06-01) - TM02
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-18) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-12-18) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-22) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-22) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-17) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-11-20) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-05-26) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-01-09) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-10-26) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-05-26) - CH03
-
change-person-director-company (2017-05-30) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-23) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-28) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-06-28) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-25) - AD01
-
capital-allotment-shares (2016-05-10) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-10) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-23) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-24) - MR01
-
incorporation-company (2015-05-26) - NEWINC
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-07-01) - AP03
-
capital-allotment-shares (2015-07-06) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-10-17) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-03) - TM01