-
STELLAR (ECLIPSE) HOLDINGS LIMITED - 3rd, Floor South Building, 200 Aldersgate Street, London, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09599616
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd
- Floor South Building
- 200 Aldersgate Street
- London
- EC1A 4HD
- England 3rd, Floor South Building, 200 Aldersgate Street, London, EC1A 4HD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DOUGLASS, Charlotte Sophie Ellen
- MCKEOWN, Sean Thomas
- MOYLE, Robert Bromley
- VIVIES, Brice
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.05.2015
- Alter der Firma 2015-05-19 9 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Hfi Investments Limited
- Wr Hatfield Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- FUSION CARDIFF METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-27
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-02
- Letzte Einreichung: 2019-05-19
-
STELLAR (ECLIPSE) HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- STELLAR (ECLIPSE) HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09599616. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.05.2015 registriert. STELLAR (ECLIPSE) HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FUSION CARDIFF METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 3Rd erreicht werden.
Jetzt sichern STELLAR (ECLIPSE) HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stellar (Eclipse) Holdings Limited - 3rd, Floor South Building, 200 Aldersgate Street, London, Grossbritannien
- 2015-05-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STELLAR (ECLIPSE) HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-03-28) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2020-02-25) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-02) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-01-02) - PSC05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-07) - AP01
-
resolution (2019-01-11) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2019-01-16) - SH02
-
second-filing-capital-allotment-shares (2019-02-11) - RP04SH01
-
legacy (2019-02-12) - ALLOTCORR
-
resolution (2019-02-15) - RESOLUTIONS
-
legacy (2019-02-15) - CAP-SS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-02-15) - SH19
-
legacy (2019-02-15) - SH20
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-22) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-27) - AA01
-
capital-allotment-shares (2019-01-14) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-02) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-21) - MR01
-
resolution (2018-12-20) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-11-13) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-22) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-04) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-12-22) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
memorandum-articles (2016-01-29) - MA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-18) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-11) - AP01
-
resolution (2016-01-29) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-07-11) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-09) - MR01
-
incorporation-company (2015-05-19) - NEWINC