-
NEXUS DRY HIRE LIMITED - Unit H2 Redwood Court, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09590906
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit H2 Redwood Court
- Tytherington Business Park
- Macclesfield
- Cheshire
- SK10 2XH
- England Unit H2 Redwood Court, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2XH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- AGAR, Thomas Mathew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.05.2015
- Alter der Firma 2015-05-14 9 Jahre
- SIC/NACE
- 77390
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Thomas Mathew Agar
- Evogo Group Ltd
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-05-29
- Letzte Einreichung: 2024-05-15
-
NEXUS DRY HIRE LIMITED Firmenbeschreibung
- NEXUS DRY HIRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09590906. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.05.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77390" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit H2 Redwood Court erreicht werden.
Jetzt sichern NEXUS DRY HIRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nexus Dry Hire Limited - Unit H2 Redwood Court, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire, Grossbritannien
- 2015-05-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEXUS DRY HIRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-01-19) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2024-05-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-09-26) - AA
-
legacy (2023-09-26) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-09-26) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-09-26) - AGREEMENT2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2022-07-12) - AA
-
legacy (2022-07-12) - PARENT_ACC
-
legacy (2022-07-12) - GUARANTEE2
-
legacy (2022-07-12) - AGREEMENT2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-07-20) - AA
-
legacy (2021-07-20) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-07-20) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-07-20) - AGREEMENT2
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-03-18) - MR01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-01-19) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-14) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-14) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-14) - PSC02
-
legacy (2020-10-23) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-10-23) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-11-26) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-12-02) - AA
-
legacy (2020-11-26) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-11-26) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-23) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-02) - PSC05
-
capital-allotment-shares (2019-05-02) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-09-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-17) - AA
-
legacy (2018-10-04) - GUARANTEE2
-
legacy (2018-10-04) - AGREEMENT2
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-05-09) - PSC04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-13) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-07-06) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-16) - AP01
-
capital-allotment-shares (2017-06-09) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-15) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-01-31) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-10) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-24) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-05-14) - NEWINC