-
K & H DESIGN LIMITED - 2-4 Packhorse Road, Gerrards Cross, Buckinghamshire, SL9 7QE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09578932
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2-4 Packhorse Road
- Gerrards Cross
- Buckinghamshire
- SL9 7QE
- England 2-4 Packhorse Road, Gerrards Cross, Buckinghamshire, SL9 7QE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GLAISTER, Catherine Victoria Jane
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.05.2015
- Alter der Firma 2015-05-07 9 Jahre
- SIC/NACE
- 74100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Catherine Glaister
- -
- Mrs Catherine Victoria Jane Glaister
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-02-29
- Letzte Einreichung: 2022-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-21
- Letzte Einreichung: 2023-05-07
-
K & H DESIGN LIMITED Firmenbeschreibung
- K & H DESIGN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09578932. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.05.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2-4 Packhorse Road erreicht werden.
Jetzt sichern K & H DESIGN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: K & H Design Limited - 2-4 Packhorse Road, Gerrards Cross, Buckinghamshire, SL9 7QE, Grossbritannien
- 2015-05-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu K & H DESIGN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
capital-cancellation-shares (2023-05-24) - SH06
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2023-05-27) - RP04CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-05-09) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2023-05-11) - SH03
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-05-15) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-05-15) - PSC04
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-30) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-08-09) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-17) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-04-13) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-04-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-14) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-14) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-20) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-15) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-16) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-14) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-06-18) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-22) - AA
-
resolution (2018-06-12) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-12) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-06-01) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-08-15) - DISS40
-
capital-allotment-shares (2017-08-11) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-14) - PSC01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-08-14) - AP03
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-08-11) - SH08
-
resolution (2017-08-09) - RESOLUTIONS
-
gazette-notice-compulsory (2017-07-25) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-09-02) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-09-02) - SH08
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-05-07) - NEWINC