-
FIVE MILE DRIVE HOLDINGS LIMITED - Moorgate House, 201 Silbury Boulevard, Milton Keynes, MK9 1LZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09566603
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Moorgate House
- 201 Silbury Boulevard
- Milton Keynes
- MK9 1LZ
- England Moorgate House, 201 Silbury Boulevard, Milton Keynes, MK9 1LZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MCCARTIE, Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.04.2015
- Alter der Firma 2015-04-29 9 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Pmc Ventures Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-05-13
- Letzte Einreichung: 2024-04-29
-
FIVE MILE DRIVE HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- FIVE MILE DRIVE HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09566603. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.04.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Moorgate House erreicht werden.
Jetzt sichern FIVE MILE DRIVE HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Five Mile Drive Holdings Limited - Moorgate House, 201 Silbury Boulevard, Milton Keynes, MK9 1LZ, Grossbritannien
- 2015-04-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FIVE MILE DRIVE HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
change-person-director-company-with-change-date (2024-01-31) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-05-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-12-16) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2023-11-28) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-24) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-08-07) - PSC05
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-07) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-05) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-14) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-01) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-21) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-21) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-10-28) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-21) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-08-10) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-07-24) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-06-19) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-13) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-04-01) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-22) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-01) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-20) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-06-24) - SH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-05-22) - AP03
-
incorporation-company (2015-04-29) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-21) - MR01