-
SUNNYSIDE 2 WIND TURBINE LIMITED - 1020 Eskdale Road, Winnersh, Wokingham, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09564248
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1020 Eskdale Road
- Winnersh
- Wokingham
- Berkshire
- RG41 5TS 1020 Eskdale Road, Winnersh, Wokingham, Berkshire, RG41 5TS UK
Management
- Geschäftsführung
- ROSE, David Rowley
- Prokuristen
- AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.04.2015
- Alter der Firma 2015-04-28 9 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-26
- Letzte Einreichung: 2019-06-12
-
SUNNYSIDE 2 WIND TURBINE LIMITED Firmenbeschreibung
- SUNNYSIDE 2 WIND TURBINE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09564248. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.04.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 1020 Eskdale Road erreicht werden.
Jetzt sichern SUNNYSIDE 2 WIND TURBINE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sunnyside 2 Wind Turbine Limited - 1020 Eskdale Road, Winnersh, Wokingham, Berkshire, Grossbritannien
- 2015-04-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SUNNYSIDE 2 WIND TURBINE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-09-21) - LIQ13
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-09) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-26) - AD01
-
resolution (2019-09-25) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-09-25) - LIQ01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-06) - TM01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-09-25) - 600
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-05) - AP01
-
capital-allotment-shares (2019-07-08) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-02) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-24) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-20) - PSC07
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-15) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-15) - PSC02
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-09-19) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-21) - AA
-
resolution (2017-11-16) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-09) - PSC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-07) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-07) - AP01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2017-11-06) - AP04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-06) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-11) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-11) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-24) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-24) - AAMD
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-26) - AAMD
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-29) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-11) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-11) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-09) - MR01
-
incorporation-company (2015-04-28) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-21) - MR01