-
DRYWALL QATAR UK LIMITED - Berners House, 47-48 Berners Street, London, W1T 3NF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09552311
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Berners House
- 47-48 Berners Street
- London
- W1T 3NF
- England Berners House, 47-48 Berners Street, London, W1T 3NF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- PAPADOPOULOS, Yiannos
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.04.2015
- Gelöscht am:
- 2020-02-18
- SIC/NACE
- 43390
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Georgios Xydas
- Mr Yiannos Papadopoulos
- Mr Georgios Xydas
- Mr Yiannos Papadopoulos
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2016-04-30
-
DRYWALL QATAR UK LIMITED Firmenbeschreibung
- DRYWALL QATAR UK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09552311. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 21.04.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43390" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Berners House erreicht werden.
Jetzt sichern DRYWALL QATAR UK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Drywall Qatar Uk Limited - Berners House, 47-48 Berners Street, London, W1T 3NF, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DRYWALL QATAR UK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-compulsory (2020-02-18) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-07-03) - TM02
-
gazette-notice-compulsory (2019-07-02) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-08-10) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-17) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-21) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-22) - PSC02
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-02-03) - DISS40
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-notice-compulsory (2017-12-05) - GAZ1
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2017-10-19) - AP04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-21) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-04-21) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-31) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-31) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-28) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-10-25) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-07-02) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-22) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-06-22) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-19) - AP01
-
incorporation-company (2015-04-21) - NEWINC