-
ACTIVE MANAGEMENT SOLUTIONS (5) LIMITED - Apartment 13 38 Paradise Street, Birmingham, West Midlands, B1 2AF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09547670
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Apartment 13 38 Paradise Street
- Birmingham
- West Midlands
- B1 2AF
- England Apartment 13 38 Paradise Street, Birmingham, West Midlands, B1 2AF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HANCOCK, James Oliver
- CHERRY, Robert Charles Rolf
- Prokuristen
- WRIGHT, Christopher
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.04.2015
- Alter der Firma 2015-04-17 9 Jahre
- SIC/NACE
- 52103
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Willow Assetco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-03-13
- Letzte Einreichung: 2024-02-27
-
ACTIVE MANAGEMENT SOLUTIONS (5) LIMITED Firmenbeschreibung
- ACTIVE MANAGEMENT SOLUTIONS (5) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09547670. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.04.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52103" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Apartment 13 38 Paradise Street erreicht werden.
Jetzt sichern ACTIVE MANAGEMENT SOLUTIONS (5) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Active Management Solutions (5) Limited - Apartment 13 38 Paradise Street, Birmingham, West Midlands, B1 2AF, Grossbritannien
- 2015-04-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ACTIVE MANAGEMENT SOLUTIONS (5) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-02-14) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2024-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-09-27) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-04-25) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-09) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-03-05) - PSC05
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-09-26) - AA
-
resolution (2022-08-25) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2022-08-25) - MA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-24) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-03-24) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-03-24) - TM01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2022-03-24) - PSC09
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-04-09) - MR01
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-05-07) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-10-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-09) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-21) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
second-filing-capital-allotment-shares (2017-03-15) - RP04SH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-20) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-05-12) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-03-03) - SH01
-
capital-allotment-shares (2016-12-05) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-31) - AP01
-
resolution (2016-06-02) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-23) - AR01
-
capital-allotment-shares (2016-05-16) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-05-16) - SH02
-
capital-allotment-shares (2016-04-22) - SH01
-
capital-allotment-shares (2016-04-13) - SH01
-
capital-allotment-shares (2016-02-23) - SH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-01-18) - AP03
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-04-17) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-04) - MR01