-
CWE V27 LIMITED - First Floor River Court The Old Mill Office Park, Mill Lane, Godalming, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09534606
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- First Floor River Court The Old Mill Office Park
- Mill Lane
- Godalming
- Surrey
- GU7 1EZ
- England First Floor River Court The Old Mill Office Park, Mill Lane, Godalming, Surrey, GU7 1EZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- AKERS-DOUGLAS, Dominic Lovett
- HUTT, Bruce John Alexander
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.04.2015
- Alter der Firma 2015-04-09 9 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Cwe B Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- KINETICA 735 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-23
- Letzte Einreichung: 2020-04-09
-
CWE V27 LIMITED Firmenbeschreibung
- CWE V27 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09534606. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.04.2015 registriert. CWE V27 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen KINETICA 735 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über First Floor River Court The Old Mill Office Park erreicht werden.
Jetzt sichern CWE V27 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cwe V27 Limited - First Floor River Court The Old Mill Office Park, Mill Lane, Godalming, Surrey, Grossbritannien
- 2015-04-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CWE V27 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-01-05) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-01-11) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-01-05) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-01-05) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-01-05) - PSC02
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-15) - CS01
-
memorandum-articles (2020-05-29) - MA
-
resolution (2020-05-29) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-12-16) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-07-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-17) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-07-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-09) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-04) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-03) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-10-10) - PSC05
-
resolution (2017-12-19) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-11-15) - AA01
-
resolution (2017-11-07) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-24) - MR04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-05) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-08-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-03) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-01) - MR01
-
incorporation-company (2015-04-09) - NEWINC