-
GREEN ENERGY GEOTHERMAL INTERNATIONAL LIMITED - 3rd, Floor Cavendish House 39-41 Waterloo Street, Birmingham, B2 5PP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09512859
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd
- Floor Cavendish House 39-41 Waterloo Street
- Birmingham
- B2 5PP 3rd, Floor Cavendish House 39-41 Waterloo Street, Birmingham, B2 5PP UK
Management
- Geschäftsführung
- ENGER, Thorleif
- LAUGERUD, Terje
- MCNAUGHT-DAVIS, James
- NILSEN, Torkjell Johan
- SPERLING, Joerg Jacques
- Prokuristen
- HARRIS, Peter John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.03.2015
- Gelöscht am:
- 2022-12-20
- SIC/NACE
- 64209
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-04-09
- Letzte Einreichung: 2018-03-26
-
GREEN ENERGY GEOTHERMAL INTERNATIONAL LIMITED Firmenbeschreibung
- GREEN ENERGY GEOTHERMAL INTERNATIONAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09512859. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 26.03.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 3Rd erreicht werden.
Jetzt sichern GREEN ENERGY GEOTHERMAL INTERNATIONAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Green Energy Geothermal International Limited - 3rd, Floor Cavendish House 39-41 Waterloo Street, Birmingham, B2 5PP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GREEN ENERGY GEOTHERMAL INTERNATIONAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-04-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-09-28) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-07-24) - AM10
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2019-07-24) - AM22
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-02-14) - AM10
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2019-01-19) - AM02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-08-12) - 600
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2018-09-20) - AM07
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-09-04) - AM03
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-07-27) - AM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-04-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-11) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-04-10) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-03-29) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-17) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-17) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-31) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-06-30) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-29) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-28) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-05) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-06-29) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-10-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-19) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-08-17) - AA01
-
resolution (2015-08-21) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2015-08-21) - MA
-
capital-allotment-shares (2015-08-21) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-08-21) - SH02
-
resolution (2015-06-04) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2015-03-26) - NEWINC