-
DRAKEWEST LIMITED - C/O Azets Holdings Limited, 5th Floor, Ship Canal House, 98 King Street, Manchester, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09504666
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Azets Holdings Limited, 5th Floor
- Ship Canal House
- 98 King Street
- Manchester
- M2 4WU C/O Azets Holdings Limited, 5th Floor, Ship Canal House, 98 King Street, Manchester, M2 4WU UK
Management
- Geschäftsführung
- SHAH, Nimesh
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-23 9 Jahre
- SIC/NACE
- 69203
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Blick Rothenberg Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- WESTLETON DRAKE LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-06
- Letzte Einreichung: 2021-03-23
-
DRAKEWEST LIMITED Firmenbeschreibung
- DRAKEWEST LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09504666. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.03.2015 registriert. DRAKEWEST LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WESTLETON DRAKE LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69203" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über C/o Azets Holdings Limited, 5Th Floor erreicht werden.
Jetzt sichern DRAKEWEST LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Drakewest Limited - C/O Azets Holdings Limited, 5th Floor, Ship Canal House, 98 King Street, Manchester, Grossbritannien
- 2015-03-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DRAKEWEST LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-09-04) - AD01
-
resolution (2021-08-23) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-23) - 600
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2021-08-23) - LIQ01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-07-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-16) - CS01
-
resolution (2021-05-28) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
legacy (2020-06-19) - CAP-SS
-
resolution (2020-06-19) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-31) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-25) - CH01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-06-19) - SH19
-
legacy (2020-06-19) - SH20
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-07-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-02) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-24) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-20) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-20) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-24) - AP01
-
termination-director-company (2018-07-24) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-26) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-07-20) - AA01
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-07-27) - SH02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-31) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-03) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-14) - AA
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2017-04-28) - SH10
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-24) - CH01
-
resolution (2017-04-20) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-06) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-04-06) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-24) - AD01
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-04-28) - SH08
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-01-18) - SH08
-
resolution (2016-01-18) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-01-18) - SH01
-
memorandum-articles (2016-01-19) - MA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-14) - AR01
-
resolution (2016-04-14) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-05) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-06-16) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-10-12) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-02) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-09-30) - CH01
-
capital-allotment-shares (2015-10-06) - SH01
-
incorporation-company (2015-03-23) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2015-04-02) - CERTNM
-
capital-allotment-shares (2015-10-14) - SH01
-
capital-allotment-shares (2015-10-16) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-15) - MR01
-
resolution (2015-10-15) - RESOLUTIONS